edecideur.info

PACKPROSPECT : Boostez votre prospection BtoB


149 €

Economisez jusqu'a 80% sur vos fichiers de prospection BtoB qualifiés

Fichiers qualifiés avec nom des dirigeants - Sources officielles PACKPROSPECT.COM


Information légale sur CHANCE Jean-Marie Gérant de SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES

avatar
1 Mandat(s)
35 ans
1 établissement(s)

CHANCE Jean-Marie



Gérant de SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES



CHANCE Jean-Marie a 35 ans ( naissance en 1983), il est Gérant de la société SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES.

CHANCE Jean-Marie peut être contacté au siège de la société SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES par courrier à l'adresse 9 RUE DU BOUT AU CERF 14440 PLUMETOT

Présentation de : SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES 66382010800046 - 9 rue du bout au cerf 14440 plumetot

La société SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES est principalement dirigée par CHANCE Jean-Marie qui en est Gérant.

Cette société a pour activité principale : Interm. du comm. en m.p. agricoles & textiles, animaux vivants, intermédiaire de commerce, agent commercial, intermédiaire de commerce en matières premières agricoles, agent commercial en matières premières agricoles, intermédiaire de commerce en animaux vivants, agent commercial en animaux vivants, intermédiaire,
Activités exclus du code APE
Les entreprises dont le code ape est 4611Z ne peuvent pas faire : le commerce de gros pour compte propre (cf46.2 à 46.9) le commerce de détail par des intermédiaires du commerce hors magasin (cf47.99B) les intermédiaires du commerce en engrais et produits phytosanitaires (cf46.12B)

La société SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.. Elle a été crée le 10/02/1966 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret 66382010800046.


Rapport des réseaux d'affaires des dirigeants de SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES

CHANCE Jean-Marie

Gérant chez SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES

Adresse: 9 RUE DU BOUT AU CERF 14440 PLUMETOT
Téléphone:
Télécopie:

Les Mandats de CHANCE Jean-Marie

  • 663820108 Gérant de SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES
PACKPROSPECT Boostez votre prospection BtoB avec des fichiers qualifiés et économisez plus de 80% sur vos fichiers de prospection BtoB qualifiés

Etat juridique de SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES

Dénomination sociale SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES
Nom commercial SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES
Siren 66382010800046
TVA FR90663820108
APE 4611Z (Interm. du comm. en m.p. agricoles & textiles, animaux vivants)
Siége social 9 RUE DU BOUT AU CERF 14440 PLUMETOT
Téléphone
Télécopie
Création 10/02/1966
Forme juridique SARL unipersonnelle
Capital 60 120,00 €
Greffe CAEN
Dossier au greffe La Société SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES est du ressort du greffe de CAEN sis à l'adresse : PALAIS DE JUSTICE PLACE GAMBETTA 14037 CAEN CEDEX .

Vous pouvez contacter le greffe au 02 31 85 40 00 ou vous rendre sur son site internet à l'adresse www.greffe-tc-caen.fr.

Nom des greffiers : LEGER Francis , LEGER Aurélien , JONVAL Sophie
Horaires d'ouverture du greffe : Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
Activité Interm. du comm. en m.p. agricoles & textiles, animaux vivants
Etablissement 1

Geocodage de l'établissement principal

Adresse 9 RUE DU BOUT AU CERF
Code postal 14440
Ville PLUMETOT
Nord
Sud
Est
Ouest
X
Y
Z
adresse normalisée 9 RUE DU BOUT AU CERF
Région Normandie
Département Normandie
Localité PLUMETOT
Rue 9 RUE DU BOUT AU CERF
Code postal 14440

Données comptables

Actif au bilan
Année 2012
Actif immobilisé 4 011
Immobilisation incorporelle 0
Immobilisation corporelle 3 294
Immobilisation financière 717
Actif circulant net 145 331
Stock 42 099
Avance 0
Créance 29 562
Placement 73 670
Total Actif 149 344


Passif au bilan
Capitaux propre 117 196
Autres fonds 0
Provision 0
Dette 32 147
Total Passif 149 343


Compte de résultat
Chiffre d'affaire 134 946
Produit d'exploitation 134 723
Charge d'exploitation 131 841
Résultat d'exploitation 2 882
Produit financier net 1 350
Charge financière 0
Résultat financier 1 350
Résultat courrant 4 232
Produit exceptionnel 0
Charges exceptionnelles 0
Résultat exceptionnel 0
Résultat net 4 233

Carte

PACKPROSPECT : Boostez votre prospection BtoB


149 €

Economisez jusqu'a 80% sur vos fichiers de prospection BtoB qualifiés

Fichiers qualifiés avec nom des dirigeants - Sources officielles PACKPROSPECT.COM


10 décideurs de PLUMETOT

CHANCESOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES
HUTTEPAINSOCIETE CAENNAISE DE DISTRIBUTION
PAJOTSOCIETE CAENNAISE DE DISTRIBUTION
GEORGHIOUSOCIETE CAENNAISE DE DISTRIBUTION
HEROULTSCI LAURELIE
HEROULTSCI LAURELIE
HAMELINEARL LES PERRELLES
QUESNELSOCIETE CIVILE LES VALLEES
BUHOURSPHBTP
BUHOURSEARL BUHOURS
BRINBRIN

10 décideurs de interm. du comm. en m.p. agricoles & textiles, animaux vivants

RAZAFIMAHEFATRANSPORTS ZEPHYR
MICHET DE VARINE BOHANINTERKRAFT
PERROTAGRO 3 D
CHANCESOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES
AUDOYAGR'ESTUAIRE
MeroueENVITERRE
BadianeENVITERRE
JaberENVITERRE
BOURSETOPMER
KLINGCOMPTOIR DE PRODUITS AGRICOLES
TohmeINTRADE FRANCE

Etablissements de SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES

Siret Nom Adresse
66382010800046 SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES 9 RUE DU BOUT AU CERF 14440 PLUMETOT

Dirigeant(s) de SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES

Le dirigeant de la société SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES est :
  • Jean-Marie CHANCE Gérant

Greffe de SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES

La Société SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES est du ressort du greffe de CAEN sis à l'adresse : PALAIS DE JUSTICE PLACE GAMBETTA 14037 CAEN CEDEX .

Vous pouvez contacter le greffe au 02 31 85 40 00 ou vous rendre sur son site internet à l'adresse www.greffe-tc-caen.fr.

Nom des greffiers : LEGER Francis , LEGER Aurélien , JONVAL Sophie
Horaires d'ouverture du greffe : Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30

Conventions collectives de SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES

Les conventions collectives applicables à SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES en raison de l'enregistrement de son activité sous le code ape 4611Z Interm. du comm. en m.p. agricoles & textiles, animaux vivants sont
  • :

Timeline des événements et des actes

  • Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège social

    jeudi 01 janvier 1970
  • Statuts mis à jour

    jeudi 01 janvier 1970
  • Statuts à jour STATUTS A JOUR

    jeudi 01 janvier 1970
  • Modification CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE

    jeudi 01 janvier 1970
  • Modification AUGMENTATION DE CAPITAL

    jeudi 01 janvier 1970
  • Modification

    jeudi 01 janvier 1970
  • Modification PV D'ASSEMBLEE

    jeudi 01 janvier 1970
  • Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration

    jeudi 01 janvier 1970
  • Modification CHANGEMENT DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    jeudi 01 janvier 1970
  • Modification MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

    jeudi 01 janvier 1970
  • Modification PV D'ASSEMBLEE

    jeudi 01 janvier 1970
  • Modification PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

    jeudi 01 janvier 1970
  • Statuts mis à jour

    jeudi 01 janvier 1970
  • Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège social

    jeudi 01 janvier 1970
  • Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration

    jeudi 01 janvier 1970
  • Modification CHANGEMENT DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    jeudi 01 janvier 1970
  • Modification MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

    jeudi 01 janvier 1970
  • Modification PV D'ASSEMBLEE

    jeudi 01 janvier 1970
  • Modification PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

    jeudi 01 janvier 1970
  • Statuts mis à jour Société pluripersonnelle devient unipersonnelle

    jeudi 01 janvier 1970
  • Procès-verbal d'assemblée générale Changement(s) de gérant(s)

    jeudi 01 janvier 1970
  • Statuts mis à jour

    jeudi 01 janvier 1970
  • Divers Divers

    jeudi 01 janvier 1970
  • Procès-verbal d'assemblée

    jeudi 01 janvier 1970
  • Procès-verbal d'assemblée

    jeudi 01 janvier 1970
  • Procès-verbal du conseil d'administration

    jeudi 01 janvier 1970
  • Procès-verbal d'assemblée

    jeudi 01 janvier 1970
  • Procès-verbal du conseil d'administration

    jeudi 01 janvier 1970
  • Depot des comptes Cloture du 2007-12-31

    dimanche 06 juillet 2008
  • Depot des comptes Cloture du 2008-12-31

    jeudi 03 septembre 2009
  • Modification Transfert de l'établissement principal, transfert du siège social

    jeudi 15 octobre 2009
  • Depot des comptes Cloture du 2009-12-31

    lundi 22 novembre 2010
  • Depot des comptes Cloture du 2010-12-31

    mercredi 21 septembre 2011
  • Depot des comptes Cloture du 2011-12-31

    mardi 18 septembre 2012
  • Depot des comptes Cloture du 2012-12-31

    lundi 14 octobre 2013
  • Depot des comptes Cloture du 2013-12-31

    samedi 18 avril 2015
  • Depot des comptes Cloture du 2014-12-31

    mardi 04 août 2015
  • Depot des comptes Cloture du 2015-12-31

    vendredi 26 août 2016
  • Modification Modification survenue sur l'administration

    vendredi 24 février 2017
  • Depot des comptes Cloture du 2016-12-31

    mardi 08 août 2017

Tags

MORAND Sébastien FERRARI Luc, François, Fernand DANGERMA Nirujan BALASUNDARAM Pierre BERNARD Denise LANGLAIS Marine HERMAND Adem BAS Jérôme FINAZ de VILLAINE Gerard CANIVEZ Nelson MASCATE Jacques DESMETTRE Julien ERRERA Aurélia KOLAR THISQUEN Marie-Thérèse Antoinette PERRIN John DERSLEY Cécilia BADAUD Séverin, Elie, Flavien BLANC Adil LAARIF Claude RANGLARET Mathias LUFT Francois Albert JACQUET Marc Seraphin PERIN MOISES DOS SANTOS FERREIRA Francis PERRET Pascal GURREA Sébastien MIDOL JACQUES PIERRE ROBERT VAQUIER MICHEL PAUL ANDRE FROGE Fernande SMILA Mathilde Marie Nicole SOUCHET PATRICK, MARC, ANDRE GOMONT Michel CORREIA Jean-Marc, Charles SURIC Vitorino DE OLIVEIRA SILVA Karine BINCOLETTO ALAIN LAVANDIER Jean-Marc GUEZET Bernard François MEYNET EDDY MICHEL REGIS PESQUEREL Franck POYET Laurent BOULE Franck Sébastien DEBORD Claudia RAYMOND Sebastien FABRY Patrick ZANNOLFI Renaud BIGNON Fathia ALCINA Pierre Meignen Nicolas KONIG Eric Gilbert Claude VIGOUROUX Stéphanie SCHULMAN Waqar SAFDAR Carole MELANIE Michèle LACROIX ABDUL HAMID KHAN LODHI QAZI Jacques DE FOUCAULD Steve LEVAVASSEUR Sandra Michelle TOURNEREAU David Da Silva Lopes Mélinda Christelle Mélanie BOUCHARIN Olivier CHOMIS Dilek BILDIK Devis CRACCO Aline VERROUST (Gilles Jacques Pierre) DOUCET Nicolas DESORME France, Lise AHMED BEN ALI Patricia KNITTEL Miguel POIRAUD Olivier Jean Pierre THEBAUT Françoise MARECHAL Jean-Luc QUETTIER Laurent FERRY Jean Daniel LEVY Daniel Jean Marie Alain LEFORT Jean-Pierre Decock Christophe CASTEL Alain GONNET Stephanie COLAGHI Abtine NOURI Pierre GEORGE Leonie LOYAU Viviane STINTZY Melody AUCHEDE Yvon DOMINIQUE Patrick TOUATI Jean PELLAE Jean-Pierre LIGETI Corrine CHERVIN Philippe BOURRAT Marc Boillot Jessee Richard CASAN Olivier BABINET Loris

Nouveau ! Recherche familiale sur le nom du dirigeant

Annuaire du téléphone :   Recherche des numéros de téléphone de tous les CHANCE de France.


© 2010-2023 - Blue Shield Publishing, inc. - All Rights Reserved. - Présentation de CHANCE Jean-Marie, Gérant de SOCIETE CAENNAISE DE COURTAGES le 28/09/2023 Version en cache du 02/10/2018 02:00:00.
PACKPROSPECT Boostez votre prospection BtoB avec des fichiers qualifiés et économisez plus de 80% sur vos fichiers de prospection BtoB qualifiés