Adresse | 123 QUAI JULES GUESDE |
Code postal | 94400 |
Ville | VITRY SUR SEINE |
Nord | |
Sud | |
Est | |
Ouest | |
X | |
Y | |
Z | |
adresse normalisée | 123 QUAI JULES GUESDE |
Région | Île-de-France |
Département | Île-de-France |
Localité | VITRY SUR SEINE |
Rue | 123 QUAI JULES GUESDE |
Code postal | 94400 |
Information légale sur SCHULER Concettina Gérant de SOCIETE D EXPLOITATION DE SUPERMARCHES DES LINANDES
SCHULER Concettina
Gérant de SOCIETE D EXPLOITATION DE SUPERMARCHES DES LINANDES
SCHULER Concettina a 57 ans ( naissance en 1961), elle est Gérant de la société SOCIETE D EXPLOITATION DE SUPERMARCHES DES LINANDES.
SCHULER Concettina peut être contacté au siège de la société SOCIETE D EXPLOITATION DE SUPERMARCHES DES LINANDES par courrier à l'adresse 123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY SUR SEINE, par téléphone au 01 30 31 10 31
Présentation de : SOCIETE D EXPLOITATION DE SUPERMARCHES DES LINANDES 31052018400113 - 123 quai jules guesde 94400 vitry sur seine 01 30 31 10 31
La société SOCIETE D EXPLOITATION DE SUPERMARCHES DES LINANDES est principalement dirigée par SCHULER Concettina qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Supermarchés, sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales,
Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du les activités des sièges sociaux les activités des sièges administratifs centralisés les activités des sièges d'entreprise les activités des bureaux locaux et régionaux les activités de gestion des filiales
Activités exclus du code APE
Les entreprises dont le code ape est 4711D ne peuvent pas faire : les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société SOCIETE D EXPLOITATION DE SUPERMARCHES DES LINANDES SOCIETE D EXPLOITATION DE SUPERMARCHES DES LINANDES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.. Elle a été crée le 28/06/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret 31052018400113.
Rapport des réseaux d'affaires des dirigeants de SOCIETE D EXPLOITATION DE SUPERMARCHES DES LINANDES
SCHULER Concettina
Gérant chez SOCIETE D EXPLOITATION DE SUPERMARCHES DES LINANDESAdresse: 123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY SUR SEINE
Téléphone: 01 30 31 10 31
Télécopie:
Les Mandats de SCHULER Concettina
- 384624888 Président de JOAN
- 504052051 Gérant de LEADER SEYNE
- 502347024 Gérant non associé de LISUD
- 403731250 Gérant de SOVIVO
- 453657181 Gérant de DISTHELIS
- 552012221 Gérant de CENTRAL VIANDES COMESTIBLES
- 493043111 Gérant de LEADER DISTRIBUTION CHATILLON SUR LOIRE
- 452675481 Gérant de AQUIPAIN
- 389825266 Gérant de MONTADIS
- 532075520 Gérant de LAFI EXPERTISE RH
- 504850546 Gérant de SOGI SILLEDISTRIBUTION
- 414085399 Gérant de DISNOR
- 480607100 Président de LEADER DISTRIBUTION SUD VENDEE
- 519023485 Gérant de PROVENCE DISCOUNT 2
- 478269749 Gérant de LEADER DISTRIBUTION BRESSUIRE
- 399753797 Gérant de LEADER PRICE ARCUEIL
- 508773215 Gérant de LEADER DISTRIBUTION BASSE MARCHE
- 419695341 Président de LEADER PRICE EXPLOITATION
- 425050473 Gérant de LEADER DISTRIBUTION SAINT LEONARD
- 403489487 Président de LEADER JUAN
- 489969667 Gérant de VIRY DISTRIBUTION
- 303765291 Président du conseil de surveillance de GEIMEX
- 401789144 Gérant de FERLEAD
- 520243197 Président de LEADER PRICE LUCON
- 520529298 Président de LEADER PRICE ANGERS
- 439774001 Gérant de LEADER DISTRIBUTION MASSIF CENTRAL
- 339927949 Gérant de SOC DISTRIBUTION SAINT OUEN
- 452576143 Gérant de COVIPAIN
- 502263163 Gérant de LEADER PRICE EXPANSION
- 399522002 Gérant de EPIDISC
- 443054523 Gérant de DISTRIMOUR
- 524094224 Président de LEADER PRICE MAGASIN 1
- 452583727 Gérant de LEADER DORDOGNE DISTRIBUTION
- 444081251 Gérant de DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE CAEN
- 388838617 Gérant de MONTAUB
- 524094257 Président de LEADER PRICE HARDRICOURT
- 503727141 Gérant de DISTRINICE
- 413696394 Gérant de LEADER DISTRIBUTION GUERET
- 478378219 Gérant de LEADER PRICE LOIR ET CHER
- 722060845 Gérant de SOGELPH S A
- 518781950 Gérant de LAFI SERVICES
- 453322026 Gérant de LEADER DISTRIBUTION LES MARTINES
- 392077954 Gérant de RETAIL LEADER PRICE INVESTISSEMENT
- 390672855 Gérant de B2D
- 507809192 Gérant de LEADER PRICE SARTHE
- 423749282 Gérant de SARL EFFEL
- 414265165 Président de DISTRIBUTION FRANPRIX
- 752101733 Gérant de LP POTEAU
- 478466568 Gérant de LEADER DISTRIBUTION AMBAZAC
- 401768957 Gérant de SEMBAT DISTRIBUTION
- 512376195 Gérant de PROLEADER
- 419866074 Gérant de LEADER SAINT CERE
- 438968232 Gérant de GENDIS
- 310520184 Gérant de SOCIETE D EXPLOITATION DE SUPERMARCHES DES LINANDES
- 437582166 Gérant de CENTRALEFI
- 501398127 Gérant de LEADER MELUN
- 397945064 Gérant de LEADER DISTRIBUTION BEL AIR
- 410452072 Président de LEADER DISTRIBUTION SEVRE NIORTAISE
- 524094208 Président de LEADER PRICE MAGASIN 5
- 414546150 Gérant de DISMONT
- 440113405 Gérant de LEADER FIGEAC DISTRIBUTION
Etat juridique de SOCIETE D EXPLOITATION DE SUPERMARCHES DES LINANDES
Dénomination sociale | SOCIETE D EXPLOITATION DE SUPERMARCHES DES LINANDES |
Nom commercial | SOCIETE D EXPLOITATION DE SUPERMARCHES DES LINANDES |
Siren | 31052018400113 |
TVA | FR15310520184 |
APE | 4711D (Supermarchés) |
Siége social | 123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY SUR SEINE |
Téléphone | 01 30 31 10 31 |
Télécopie | |
Création | 28/06/2010 |
Forme juridique | SARL unipersonnelle |
Capital | 40 000,00 € |
Greffe | CRETEIL |
Dossier au greffe | La Société SOCIETE D EXPLOITATION DE SUPERMARCHES DES LINANDES est du ressort du greffe de CRETEIL sis à l'adresse : CENTRE COMMERCIAL DE CRETEIL SOLEIL 94049 CRETEIL CEDEX. Vous pouvez contacter le greffe au 01 43 99 10 07 ou vous rendre sur son site internet à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr. Nom des greffiers : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie Horaires d'ouverture du greffe : Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h |
Activité | Supermarchés |
Etablissement | 7 |
Geocodage de l'établissement principal
Données comptables
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 3 950 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 472 000 |
Immobilisation corporelle | 1 427 000 |
Immobilisation financière | 51 000 |
Actif circulant net | 1 101 000 |
Stock | 751 000 |
Avance | 0 |
Créance | 335 000 |
Placement | 15 000 |
Total Actif | 5 052 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -668 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 94 000 |
Dette | 5 626 000 |
Total Passif | 5 052 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 11 280 000 |
Produit d'exploitation | 11 336 000 |
Charge d'exploitation | 12 554 000 |
Résultat d'exploitation | -1 219 000 |
Produit financier net | 7 000 |
Charge financière | 61 000 |
Résultat financier | -54 000 |
Résultat courrant | -1 273 000 |
Produit exceptionnel | 257 000 |
Charges exceptionnelles | 279 000 |
Résultat exceptionnel | -21 000 |
Résultat net | -1 294 000 |
Etablissements de SOCIETE D EXPLOITATION DE SUPERMARCHES DES LINANDES
Siret | Nom | Adresse |
---|---|---|
31052018400113 | SOCIETE D EXPLOITATION DE SUPERMARCHES DES LINANDES | 123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY SUR SEINE |
31052018400097 | SOC D EXPLOIT SUPERMARCHES LINANDES LEADER PRICE 2 RUE JULES FERRY 47190 AIGUILLON FRANCE | |
31052018400055 | SOC D EXPLOIT SUPERMARCHES LINANDES LEADER PRICE ANGLE CHEMIN DU BAS 168 AVENUE DE LA LIBERATION 33410 BEGUEY FRANCE | |
31052018400071 | SOC D EXPLOIT SUPERMARCHES LINANDES LEADER PRICE 117 AVENUE JEAN JAURES 47200 MARMANDE FRANCE | |
31052018400063 | SOC D EXPLOIT SUPERMARCHES LINANDES LEADER PRICE RUE JEAN MERMOZ BOULEVARD VICTOR HUGO 47800 MIRAMONT DE GUYENNE FRANCE | |
31052018400105 | SOC D EXPLOIT SUPERMARCHES LINANDES LEADER PRICE AU LIEU DIT POVILLE 47400 TONNEINS FRANCE | |
31052018400089 | SOC D EXPLOIT SUPERMARCHES LINANDES LEADER PRICE 68 AVENUE DE FUMEL 47300 VILLENEUVE SUR LOT FRANCE |
Dirigeant(s) de SOCIETE D EXPLOITATION DE SUPERMARCHES DES LINANDES
Greffe de SOCIETE D EXPLOITATION DE SUPERMARCHES DES LINANDES
Vous pouvez contacter le greffe au 01 43 99 10 07 ou vous rendre sur son site internet à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Nom des greffiers : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Horaires d'ouverture du greffe : Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h
Conventions collectives de SOCIETE D EXPLOITATION DE SUPERMARCHES DES LINANDES
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 : Commerces de gros
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 : Hospitalisation privée
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 : Immobilier
- 01388 : Industrie du pétrole
- 00176 : Industrie pharmaceutique
- 00044 : Industries chimiques
- 00650 : Métallurgie cadres
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 : Promotion construction
- 01501 : Restauration rapide
- 01090 : Services de l'automobile
- 00016 : Transports routiers
- 01413 : Travail temporaire permanents
- 02409 : Travaux publics cadres
Timeline des événements et des actes
-
Décision(s) de l'associé uniquejeudi 01 janvier 1970
-
Décision(s) de l'associé uniquejeudi 01 janvier 1970
-
Statuts mis à jourjeudi 01 janvier 1970
-
Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de gérant(s)jeudi 01 janvier 1970
-
Extrait de procès-verbal Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital socialjeudi 01 janvier 1970
-
Statuts mis à jourjeudi 01 janvier 1970
-
Acte sous seing privé Cession ou donation de partsjeudi 01 janvier 1970
-
Décision(s) de l'associé uniquejeudi 01 janvier 1970
-
Statuts mis à jourjeudi 01 janvier 1970
-
Acte sous seing privé Cession ou donation de partsjeudi 01 janvier 1970
-
Acte sous seing privé Cession ou donation de partsjeudi 01 janvier 1970
-
Statuts mis à jourjeudi 01 janvier 1970
-
Décision(s) de l'associé unique Transfert du siège social d'un greffe extérieurjeudi 01 janvier 1970
-
Liste des sièges sociaux antérieursjeudi 01 janvier 1970
-
Statuts mis à jourjeudi 01 janvier 1970
-
Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptesjeudi 01 janvier 1970
-
Statuts mis à jourjeudi 01 janvier 1970
-
Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de gérant(s)jeudi 01 janvier 1970
-
Depot des comptes Cloture du 2007-12-31dimanche 15 juin 2008
-
Modification Modification de représentant.mercredi 25 juin 2008
-
Immatriculation Gérant : DUHAMEL Jean-Michel Françoismercredi 07 juillet 2010
-
Modification Modification de représentant.mercredi 28 juillet 2010
-
Vente Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)mercredi 11 août 2010
-
Depot des comptes Cloture du 2009-12-31lundi 04 octobre 2010
-
Depot des comptes Cloture du 2008-12-31lundi 04 octobre 2010
-
Depot des comptes Cloture du 2010-12-31jeudi 26 janvier 2012
-
Modification Modification de représentant.vendredi 08 février 2013
-
Depot des comptes Cloture du 2011-12-31lundi 11 mars 2013
-
Modification Modification de la forme juridique.jeudi 29 août 2013
-
Depot des comptes Cloture du 2012-12-31lundi 09 septembre 2013
-
Vente Autre achat, apport, attributionvendredi 18 avril 2014
-
Vente Autre achat, apport, attributiondimanche 20 avril 2014
-
Vente Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne moraledimanche 27 avril 2014
-
Vente Autre achat, apport, attributiondimanche 27 avril 2014
-
Vente Autre achat, apport, attributiondimanche 27 avril 2014
-
Vente Autre achat, apport, attributiondimanche 27 avril 2014
-
Vente Autre achat, apport, attributiondimanche 27 avril 2014
-
Vente Autre achat, apport, attributiondimanche 27 avril 2014
-
Vente Autre achat, apport, attributionmardi 27 mai 2014
-
Depot des comptes Cloture du 2014-05-26samedi 16 août 2014
-
Vente Autre achat, apport, attributionmercredi 27 août 2014
-
Depot des comptes Cloture du 2014-12-31jeudi 21 avril 2016
-
Modification Modification de représentant..jeudi 26 mai 2016
-
Vente Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)vendredi 15 juillet 2016
-
Vente Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)vendredi 19 août 2016
-
Vente Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)mardi 23 août 2016
-
Depot des comptes Cloture du 2015-12-31vendredi 02 septembre 2016
-
Modification Modification de l'adresse du siège..mardi 25 octobre 2016
-
Vente Mise en activité d'une société suite à achatmercredi 07 décembre 2016
-
Depot des comptes Cloture du 2016-12-31mercredi 04 octobre 2017
-
Modification Modification de représentant..mercredi 22 novembre 2017
-
Modification Modification du capital.dimanche 11 février 2018
Tags
Nouveau ! Recherche familiale sur le nom du dirigeant
© 2010-2024 - Blue Shield Publishing, inc. - All Rights Reserved. - Présentation de SCHULER Concettina, Gérant de SOCIETE D EXPLOITATION DE SUPERMARCHES DES LINANDES le 25/04/2024 Version en cache du 25/09/2018 02:00:00.